Full history extraction about UJP GROUP s.r.o. (IČO: 60727918)

Date and time of extraction: 14 Sep 2024, 14:56 (Prague time, GMT+1)
❗ The website where you see the information below IS NO THE OFFICIAL WEBSITE of UJP GROUP s.r.o., we dont have any their contacts, we dont know them personally. Our system just can check an official data about lefal entity UJP GROUP s.r.o. from official Czech business register (Trade register of Czech republic).

Basic data

Legal entity name: UJP GROUP s.r.o.
earlier - FINGAM s.r.o. (from 20 Jun 2007 to 16 Jun 2020)
earlier - ENVIROsoft, s.r.o. (from 29 Nov 1994 to 20 Jun 2007)
Registration number (IČO): 60727918
Taxpayer Identification Number (DIČ): CZ60727918
Registration date: 29 Nov 1994
Registration number, tax payer number and registration date is static data, which never changes during all czech legal entity existence
Legal address: Česká republika, city Praha, Nad Kamínkou 1345, Zbraslav, 15600 Praha 5
earlier - Česká republika, city Třebíč, Komenského nám. 141/5, Vnitřní Město, 67401 Třebíč (from 29 Nov 1994 to 17 Mar 2008)
Authorized capital: 23 620 000 Czech crowns , paid on Not avaliable
earlier - 21 000 000 Czech crowns , paid on Not avaliable
earlier - 100 000 Czech crowns , paid on Not avaliable
Legal entity type: limited liability company (LLC or s.r.o. in czech)
Status (Good standing): Legal entity is active
State authority registered in: Court MSPH, section C, archive number 138219
earlier - Court KSBR, section C, archive number 17154 (from 29 Nov 1994 to 28 Apr 2008) ;

Actually appointed directors

Name: MILAN SEMMLER
Address of registration: Česká republika, city Praha, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6
Appointment date: 1 Jun 2019
Record created in Trade register: 20 Sep 2019
Name: OTAKAR BÁRTA
Address of registration: Česká republika, city Jevišovice, č.p. 43, 67153 Jevišovice
Appointment date: 6 Mar 2008
Record created in Trade register: 1 Feb 2017

Additional information about directors

The way director could represent a legal entity:
  • Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. (from 1 Jul 2018)

History of company directors

Name: LEO NOVÁK
Address of registration: Česká republika, city Tišnov, Štěpánova 1955, 66601 Tišnov
Appointment date: 29 Jun 2007
Removal date: 29 Jun 2018
Record created in Trade register: 22 Jul 2015
Record deleted from Trade register: 1 Jul 2018

Name: MARCEL RYCHLIK
Address of registration: Česká republika, city Praha, Demlova 1752/19, Kunratice, 14800 Praha 4
Appointment date: 4 Feb 2008
Removal date: 31 May 2019
Record created in Trade register: 27 Jul 2014
Record deleted from Trade register: 20 Sep 2019

Name: Otakar Bárta
Address of registration: Česká republika, city Jevišovice, č.p. 43, 67153 Jevišovice
Appointment date: 6 Mar 2008
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 23 Oct 2012
Record deleted from Trade register: 1 Feb 2017

Name: Otakar Bárta
Address of registration: Česká republika, city Praha, Jahodová 2702/127, Záběhlice, 10600 Praha 10
Appointment date: 6 Mar 2008
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 17 Mar 2008
Record deleted from Trade register: 23 Oct 2012

Name: Marcel Rychlík
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice
Appointment date: 4 Feb 2008
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008

Name: Marcel Rychlik
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice
Appointment date: 4 Feb 2008
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 27 Jul 2014

Name: Leo Novák
Address of registration: Česká republika, city Bučovice, Ždánská 468, 68501 Bučovice
Appointment date: 29 Jun 2007
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 20 Jun 2007
Record deleted from Trade register: 22 Jul 2015

Name: Jiří Maša
Address of registration: Česká republika, city Třebíč, Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč
Appointment date: Not avaliable
Removal date: 29 Jun 2007
Record created in Trade register: 20 Jun 1996
Record deleted from Trade register: 20 Jun 2007

Name: Miroslav Mrtvý
Address of registration: Česká republika, city Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 1076, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Appointment date: Not avaliable
Removal date: 29 Jun 2007
Record created in Trade register: 20 Jun 1996
Record deleted from Trade register: 20 Jun 2007

Name: Ing. Václav Ochotný
Address of registration: Česká republika, city Třebíč, Novodvorská 1076/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč
Appointment date: Not avaliable
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 29 Nov 1994
Record deleted from Trade register: 20 Jun 1996

Name: Pavel Poláček
Address of registration: Česká republika, city Třebíč, Okružní 898/32, Borovina, 67401 Třebíč
Appointment date: Not avaliable
Removal date: Not avaliable
Record created in Trade register: 29 Nov 1994
Record deleted from Trade register: 20 Jun 1996

Additional information about directors

The way director could represent a legal entity:
  • Jménem společnosti je oprávněn jednat každý samostatně a podepisovat vždy společně nejméně dva jednatelé. (from 17 Mar 2008 to 1 Jul 2018)
  • Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý samostatně. (from 22 Feb 2008 to 17 Mar 2008)
  • Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel. (from 29 Nov 1994 to 22 Feb 2008)

Prosecutor (Prokura)

Prosecutor (Prokura) - statutory authority of czech legal enity, but with limited powers.

Prosecutors history

There was Prosecutors in this company before, but this type of company authority was canceled at all. Anyway, there is history data about Prosecutors of this legal entity.
Name: Anton Sedlák
Address of registration: Česká republika, city Praha, Papírenská 223/18, Bubeneč, 16000 Praha 6
Appointment date: Not avaliable
Record created in Trade register: 20 Jun 1996
Record deleted from Trade register: 10 Nov 1997
Name: Jiří Maša
Address of registration: Česká republika, city Třebíč, Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč
Appointment date: Not avaliable
Record created in Trade register: 29 Nov 1994
Record deleted from Trade register: 20 Jun 1996

Actual shareholders

Shareholders individuals, active

Name: MILAN SEMMLER
Address of registration: Česká republika, city Praha, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6
Authorized capital share: 12 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 600/1181 (50,804 %)
Record created in Trade register: 11 Feb 2021

Name: OTAKAR BÁRTA
Address of registration: Česká republika, city Jevišovice, č.p. 43, 67153 Jevišovice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 1 Feb 2017

Shareholder legal entities, active

Legal entity name: OBA Investment s.r.o. (Check up data)
Registration number: 17578213 (Check up data)
State of registration: CZ - Česká republika
Legal address: Česká republika, city Jevišovice, č.p. 43, 67153 Jevišovice
Authorized capital share: 2 620 000 Czech crowns
(paid o 100 percents)
Share(%) in legal entity: 11.09 percents
Record created in Trade register: 15 Nov 2022
Legal entity name: Millenium Investment s.r.o. (Check up data)
Registration number: 11987413 (Check up data)
State of registration: CZ - Česká republika
Legal address: Česká republika, city Praha, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6
Authorized capital share: 6 000 000 Czech crowns
(paid o 100 percents)
Share(%) in legal entity: 25 percents
Record created in Trade register: 19 Jan 2022

Shareholders history

Shareholders individuals, history

Name: FRANTIŠEK VIRDZEK
Address of registration: Česká republika, city Černá Hora, Záhumenská 62, 67921 Černá Hora
Authorized capital share: 2 620 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 131/1181 (11,093 %)
Record created in Trade register: 16 Mar 2022
Record deleted from Trade register: 15 Nov 2022
Name: MIROSLAV MRTVÝ
Address of registration: Česká republika, city Příštpo, č.p. 160, 67551 Příštpo
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 1 Feb 2017
Record deleted from Trade register: 11 Feb 2021
Name: LUBOMÍR ZAHNÁŠ
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, V Podlesí 133, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 1 Feb 2017
Record deleted from Trade register: 19 Jan 2022
Name: FRANTIŠEK VIRDZEK
Address of registration: Česká republika, city Černá Hora, Brněnská 68, 67921 Černá Hora
Authorized capital share: 2 620 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 131/1181 (11,093 %)
Record created in Trade register: 3 Jul 2016
Record deleted from Trade register: 16 Mar 2022
Name: FRANTIŠEK VRÁBLÍK
Address of registration: Česká republika, city Praha, Brodského 1664/4, Chodov, 14900 Praha 4
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 1 Jul 2016
Record deleted from Trade register: 29 Jan 2019
Name: LEO NOVÁK
Address of registration: Česká republika, city Tišnov, Štěpánova 1955, 66601 Tišnov
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Jul 2015
Record deleted from Trade register: 19 Jan 2022
Name: MILAN SEMMLER
Address of registration: Česká republika, city Praha, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 16 Jul 2015
Record deleted from Trade register: 11 Feb 2021
Name: MARCEL RYCHLIK
Address of registration: Česká republika, city Praha, Demlova 1752/19, Kunratice, 14800 Praha 4
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 27 Jul 2014
Record deleted from Trade register: 29 Jan 2019
Name: Otakar Bárta
Address of registration: Česká republika, city Jevišovice, č.p. 43, 67153 Jevišovice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 23 Oct 2012
Record deleted from Trade register: 1 Feb 2017
Name: Miroslav Mrtvý
Address of registration: Česká republika, city Příštpo, č.p. 160, 67551 Příštpo
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 23 Oct 2012
Record deleted from Trade register: 1 Feb 2017
Name: Lubomír Zahnáš
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, V Podlesí 133, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 1 Feb 2017
Name: František Vráblík
Address of registration: Česká republika, city Praha, Brodského 1664/4, Chodov, 14900 Praha 4
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 1 Jul 2016
Name: Milan Semmler
Address of registration: Česká republika, city Praha, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 16 Jul 2015
Name: Marcel Rychlík
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Miroslav Mrtvý
Address of registration: Česká republika, city Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 1076, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 23 Oct 2012
Name: František Virdzek
Address of registration: Česká republika, city Černá Hora, Brněnská 68, 67921 Černá Hora
Authorized capital share: 2 620 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 131/1181 (11,093 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 3 Jul 2016
Name: Otakar Bárta
Address of registration: Česká republika, city Praha, Jahodová 2702/127, Záběhlice, 10600 Praha 10
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 23 Oct 2012
Name: Leo Novák
Address of registration: Česká republika, city Bučovice, Ždánská 468, 68501 Bučovice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 22 Feb 2008
Record deleted from Trade register: 22 Jul 2015
Name: Otakar Bárta
Address of registration: Česká republika, city Praha, Jahodová 2702/127, Záběhlice, 10600 Praha 10
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Marcel Rychlík
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Marcel Rychlik
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 150/1181 (12,701 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 27 Jul 2014
Name: Miroslav Mrtvý
Address of registration: Česká republika, city Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 1076, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Leo Novák
Address of registration: Česká republika, city Bučovice, Ždánská 468, 68501 Bučovice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Milan Semmler
Address of registration: Česká republika, city Praha, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Lubomír Zahnáš
Address of registration: Česká republika, city Jesenice, V Podlesí 133, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: František Vráblík
Address of registration: Česká republika, city Praha, Brodského 1664/4, Chodov, 14900 Praha 4
Authorized capital share: 3 000 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 1/7 (14,285 %)
Record created in Trade register: 7 Sep 2007
Record deleted from Trade register: 22 Feb 2008
Name: Bohuslav Endt
Address of registration: Česká republika, city Tuchoměřice, Ke Statenicím 105, 25267 Tuchoměřice
Authorized capital share: 100 000 Czech crowns (paid on 100 percents)
Share(%) in legal entity: 100%
Record created in Trade register: 20 Jun 2007
Record deleted from Trade register: 7 Sep 2007
Name: CHEMCOMEX, spol. s r.o.
Address of registration: Česká republika, city Praha, Pražská 810/16, Hostivař, 10200 Praha 10
Authorized capital share: 100 000 Czech crowns (paid on 100000 Czech crowns)
Share(%) in legal entity: not avaliable
Record created in Trade register: 20 Jun 1996
Record deleted from Trade register: 10 Nov 1997
Name: CHEMCOMEX, spol. s r.o.
Address of registration: Česká republika, city Praha 10, Pražská 76, Praha 10, Česká republika
Authorized capital share: 100 000 Czech crowns (paid on 100000 Czech crowns)
Share(%) in legal entity: not avaliable
Record created in Trade register: 29 Nov 1994
Record deleted from Trade register: 20 Jun 1996

Shareholder legal entities, history

Legal entity name: CHEMCOMEX, spol. s r.o. (Check up data)
Registration number: 25076451 (Check up data)
State of registration: CZ - Česká republika
Legal address: Česká republika, city Praha, Pražská 810/16, Hostivař, 10200 Praha 10
Authorized capital share: 100 000 Czech crowns
(paid on 100000 Czech crowns)
Share(%) in legal entity: not avaliable
Record created in Trade register: 10 Nov 1997
Record deleted from Trade register: 10 Nov 1997
Legal entity name: CHEMCOMEX Praha a.s. (Check up data)
Registration number: 25076451 (Check up data)
State of registration: CZ - Česká republika
Legal address: Česká republika, city Praha, Pražská 810/16, Hostivař, 10200 Praha 10
Authorized capital share: 100 000 Czech crowns
(paid on 100000 Czech crowns)
Share(%) in legal entity: not avaliable
Record created in Trade register: 10 Nov 1997
Record deleted from Trade register: 20 Jun 2007

Licences/activities of company UJP GROUP s.r.o.

Here you can find an information about all activities and licences of company UJP GROUP s.r.o., In Czech Republic all company activities previously are defined in the memorandum of legal entity (type of activities), but then every, legal entity should obtain exact licences in Czech licence register ("živnostenský úřad"). So there are two sources we show you info, one is from a memorandum of a company (type of activities), second one is from Czech licence register (licences).

Type of activities by memorandum, actual

There are ACTUAL types of activities, which is defined in memorandum of this legal entity.

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Type of activities by memorandum, history

There are HISTORY of activity types, which was earlier defined in memorandum of this legal entity.

  • testování, měření, analýzy a kontroly - (from 22 Feb 2008 to 1 Jul 2018)
  • příprava a vypracování technických návrhů - (from 22 Feb 2008 to 1 Jul 2018)
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě - (from 22 Feb 2008 to 1 Jul 2018)
  • zprostředkování obchodu a služeb - (from 22 Feb 2008 to 1 Jul 2018)
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - (from 22 Feb 2008 to 1 Jul 2018)
  • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie - (from 22 Feb 2008 to 1 Jul 2018)
  • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - (from 20 Jun 1996 to 2 Aug 2008)
  • poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) - (from 29 Nov 1994 to 1 Jul 2018)
  • automatizované zpracování dat - (from 29 Nov 1994 to 1 Jul 2018)
  • obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona - (from 29 Nov 1994 to 1 Jul 2018)
  • školení v oblasti výpočetní techniky a s tím související činno- sti, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona - (from 29 Nov 1994 to 1 Jul 2018)

Licences by Czech licence register, actual

Actual licences of legal entity, which was obtained in Czech licence register ("živnostenský úřad").

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    • Testování, měření, analýzy a kontroly - (valid from 2008-07-01)
    • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - (valid from 2008-07-01)
    • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - (valid from 2008-07-01)
    • Zprostředkování obchodu a služeb - (valid from 2008-07-01)
    • Velkoobchod a maloobchod - (valid from 2008-07-01)
    • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - (valid from 2008-07-01)
    • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - (valid from 2008-07-01)
    • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - (valid from 2008-07-01)
    • Výroba zdravotnických prostředků - (valid from 2020-12-21)
    • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření - (valid from 2020-12-21)
    • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - (valid from 2020-12-21)
    • Poskytování technických služeb - (valid from 2020-12-21)

Licences by Czech licence register, history

History of licences of this legal entity, which was obtained in Czech licence register ("živnostenský úřad"), but which now is no more valid by now.

  • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie (from 2007-12-10 to 2008-06-30)
  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě (from 2007-12-10 to 2008-06-30)
  • Testování, měření, analýzy a kontroly (from 2007-12-10 to 2008-06-30)
  • Příprava a vypracování technických návrhů (from 2007-12-10 to 2008-06-30)
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (from 2007-12-10 to 2008-06-30)
  • Zprostředkování obchodu a služeb (from 2007-12-10 to 2008-06-30)
  • Školení v oblasti výpočetní techniky a s tím související činnosti,vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona (from 1994-11-29 to 2008-06-30)
  • Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů (from 1995-08-23 to 1996-12-10)
  • Poskytování software(prodej hotových programů a základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) (from 1994-11-29 to 2008-06-30)
  • Automatizované zpracování dat (from 1994-11-29 to 2008-06-30)
  • Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona (from 1994-11-29 to 2008-06-30)

Other information about legal entity

  • Na základě projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 24. 5. 2018 schváleného rozhodnutím valné hromady společnosti FINGAM s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 10, IČ: 607 27 918, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 138219, dne 29. 6. 2018, došlo k odštěpení části jmění společnosti FINGAM s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 10, IČ: 607 27 918, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 138219, a přechodu vyčleněné části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost FINGAM-VF s.r.o., se sídlem Nad Kamínkou 1345, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Identifikační číslo: 072 56 507. (valid from from 1 Jul 2018)
  • Společnost FINGAM s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 10, Identifikační číslo: 607 27 918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138219, byla jako společnost rozdělovaná rozdělena odštěpením se vznikem jedné nové společnosti a odštěpená část jejího jmění přešla na nově vzniklou společnost FINGAM-CHEM s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 00, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, který byl schválen rozhodnutím valné hromady dne 12.1.2017. (valid from from 1 Feb 2017)
  • Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (valid from from 15 May 2014)
  • Počet členů statutárního orgánu: 3 (valid from from 15 May 2014)
  • Společnost FINGAM s.r.o., se sídlem Praha 5, Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 10, IČ: 607 27 918 ( nástupnická společnost), se v důsledku vnitrostátní fúze sloučila se společností LKMŠ, a.s., se sídlem Praha 5, Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 10,IČ: 290 60 125, a společností VF instruments, a.s., se sídlem Černá Hora, Svitavská 588, PSČ 679 21, IČ: 272 59 790 ( zanikající společnosti). Na společnost FINGAM s.r.o. přešlo obchodní jmění společnosti LKMŠ, a.s. a společnosti VF instruments, a.s. , včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. (valid from from 31 Dec 2011)


The website where you see this extraction is not an official website of UJP GROUP s.r.o.. On this page you just see an information about that company, that we were able to finde in Czech official sources using our Czech company search system. Our system can verify official data of any Czech legal entity, but we are not connected with them and this website is not a website of UJP GROUP s.r.o.. We don't know this company personally, we can't approve (or disprove) their trustworthiness, we don't have any contacts with them. Our system is able just verify their official data.